Connecticut State Treasurer - Biblioteka.sk

Upozornenie: Prezeranie týchto stránok je určené len pre návštevníkov nad 18 rokov!
Zásady ochrany osobných údajov.
Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasím


Panta Rhei Doprava Zadarmo
...
...


A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Connecticut State Treasurer
 ...
State Treasurer of Connecticut
Seal of the State Treasurer
Incumbent
Erick Russell
since 2023
Formation1639
First holderThomas Welles
Websiteportal.ct.gov/OTT

The Connecticut State Treasurer serves the office of treasurer for the state of Connecticut.

List of state treasurers

# Image Name Took office Left office Party
1 Thomas Welles 1639 1641
2 William Whiting 1641 1648
3 Thomas Welles 1648 1652
4 John Talcott, Sr. 1652 1660
5 John Talcott, Jr. 1660 1676
6 William Pitkin 1676 1679
7 Joseph Whiting 1679 1718
8 John Whiting 1718 1750
9 Nathaniel Stanly 1750 1756
10 Joseph Talcott 1756 1769
11 John Lawrence 1769 1789
12 Jedediah Huntington 1789 1790
13 Peter Colt 1790 1794
14 Andrew Kingsbury 1794 1818
15 Isaac Spencer 1818 1835
16 Jeremiah Brown 1835 1838
17 Hiram Ryder 1838 1842
18 Jabez L. White, Jr. 1842 1844
19 Joseph B. Gilbert 1844 1846
20 Alonzo W. Birge 1846 1847
21 Joseph B. Gilbert 1847 1849
22 Henry D. Smith 1849 1851
23 Thomas Clark 1851 1852
24 Edwin Stearns 1852 1854
25 Daniel Camp 1854 1855
26 Arthur B. Calef 1855 1856
27 Frederick P. Coe 1856 1857
28 Frederick S. Wildman 1857 1858
29 Lucius J. Hendee 1858 1861
30 Ezra Dean 1861 1862
31 Gabriel W. Coite 1862 1866
32 Henry G. Taintor 1866 1867
33 Edward S. Moseley 1867 1869
34 David P. Nichols 1869 1870
35 Charles M. Pond 1870 1871
36 David P. Nichols 1871 1873
37 William E. Raymond 1873 1877
38 Edwin A. Buck 1877 1879
39 Talmadge Baker 1879 1881
40 David P. Nichols 1881 January 2, 1882 Republican
41 James D. Smith 1882 1883 Republican
42 Alfred R. Goodrich 1883 1885 Democrat
43 V. B. Chamberlain 1885 1887 Republican
44 Alexander Warner 1887 1889 Republican
44 E. Stevens Henry 1889 1893 Republican
45 Marvin H. Sanger 1893 1895 Democrat
46 George W. Hodge 1895 1897 Republican
47 Charles W. Grosvenor 1897 1899 Republican
48 Charles S. Mersick 1899 1901 Republican
49 Henry H. Gallup 1901 1905 Republican
50 James F. Walsh 1905 1907 Republican
51 Freeman F. Patten 1907 1911 Republican
52 Costello Lippitt 1911 1913 Republican
53 Edward S. Roberts 1913 1915 Democrat
54 F. S. Chamberlain 1915 1919 Republican
55 G. Harold Gilpatric 1919 1924 Republican
56 Anson T. McCook 1924 1924 Republican
57 Ernest E. Rogers 1925 1929 Republican
58 Samuel R. Spencer 1929 1931 Republican
59 Roy C. Wilcox 1931 1933 Republican
60 J. William Hope 1933 1935 Republican
61 John S. Addis 1935 September 29, 1937 Democrat
62 Thomas Hewes 1937 1937 Zdroj:https://en.wikipedia.org?pojem=Connecticut_State_Treasurer
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.






Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.

Your browser doesn’t support the object tag.

www.astronomia.sk | www.biologia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.genetika.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk